-
-
ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH - Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, Germany
Company Information
- Company registration number
- HRB38158 FRANKFURT AM MAIN
- Company Status
- LIVE
- Country
- Germany
- Registered Address
- Wilhelm-Leuschner-Straße 24
- 60329 Frankfurt am Main
- Deutschland Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland DE
Management
- Managing Directors
- Andreas Franken (Geschaeftsfuehrer)
- Christian Glanz (Geschaeftsfuehrer)
- Markus Knapp (Geschaeftsfuehrer)
- Lars Knackstedt (Geschaeftsfuehrer)
- Company secretaries
- Timo Bürk (Prokura)
- Ralph Demtröder (Prokura)
- Stefan Hess (Prokura)
- Thomas Moll (Prokura)
- Dirk Käs (Prokura)
- Axel Adams (Prokura)
- Marcus Aßmuth (Prokura)
- Jasna Husic (Prokura)
- Pascal Müller (Prokura)
- Philipp Heigl (Prokura)
- Markus Günther (Prokura)
- Christopher Thorsten Jahn (Prokura)
- Oliver Kai Möser (Prokura)
- Robert Peil (Prokura)
- Stefan Ernst Theodor Richter (Prokura)
- Peter Selzer (Prokura)
Company Details
- Type of Business
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Incorporated
- 1994-03-30
- Dissolved on
- -
- Age Of Company 1994-03-30 31 years
Ownership
- Share Capital
- 4.100.000,00 EUR
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- aktuell
- -
- -
- Court
- DE/Frankfurt am Main
- Previous Names
- ATLAS Dienstleistung für Vermögensberatung GmbH
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 529900BPPQ8CAJ57CQ08
- Website
- www.dvag.com
- Email address
- [email protected]
- Phone
- +49 6923840
- Fax
- +49 692384185
-
ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH Company Description
- www.dvag.com.
Get ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract
You are here: Atlas Dienstleistungen Für Vermögensberatung Gmbh - Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329 Frankfurt am Main, Deutschland, Germany
- 1994-03-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Handelsregister
- 2023-08-17 Modification
- Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
-
ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH
Did you know? kompany provides original and official company documents for ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Shareholder List
Details on the shareholders
Articles of Association
Founding documents
Annual Account
Financial data for the last reported full year
Chronological Extract
Full record of registrable changes
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2024
-
2024-03-14 - Sonstige Urkunde Unterlage vom 14.03.2024
-
2024 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 15.12.2011 (+ Weitere Dokumente)
-
2024-01-04 - Anmeldung vom 04.01.2024
-
2024-04-22 - Anmeldung vom 22.04.2024
keyboard_arrow_right 2023
-
2023-12-28 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 28.12.2023
-
2023-08-10 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 10.08.2023
-
2023-02-06 - Anmeldung vom 06.02.2023
-
2023-02-24 - Anmeldung vom 24.02.2023
-
2023-05-08 - Anmeldung vom 08.05.2023
-
2023-06-05 - Anmeldung vom 05.06.2023
keyboard_arrow_right 2022
-
2022-01-05 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 05.01.2022
-
2022-11-03 - Anmeldung vom 03.11.2022
keyboard_arrow_right 2021
-
2021-04-23 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 23.04.2021
-
2021-04-28 - Anmeldung vom 28.04.2021
-
2021-06-16 - Anmeldung vom 16.06.2021
-
2021-09-01 - Anmeldung vom 01.09.2021
-
2021-12-17 - Anmeldung vom 17.12.2021
-
2021-02-23 - Amtsniederlegung vom 23.02.2021
-
2021-06-10 - Amtsniederlegung vom 10.06.2021
-
2021-02-03 - Anmeldung vom 03.02.2021
keyboard_arrow_right 2020
-
2020-09-30 - Dauervollmacht vom 30.09.2020
-
2020-04-08 - Anmeldung vom 08.04.2020
-
2020-09-03 - Anmeldung vom 03.09.2020
keyboard_arrow_right 2019
-
2019-06-19 - Anmeldung vom 19.06.2019
keyboard_arrow_right 2018
-
2018-11-28 - Anmeldung vom 28.11.2018
-
2018-10-19 - Anmeldung vom 19.10.2018
-
2018-08-22 - Anmeldung vom 22.08.2018
-
2018-03-29 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 29.03.2018
keyboard_arrow_right 2017
-
2017-03-30 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 30.03.2017
-
2017-10-13 - Anmeldung vom 13.10.2017
-
2017-09-13 - Anmeldung vom 13.09.2017
-
2017-03-30 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 30.03.2017
-
2017-02-03 - Anmeldung vom 03.02.2017
-
2017-02-28 - Anmeldung vom 28.02.2017
-
2017-04-27 - Anmeldung vom 27.04.2017
-
2017-07-05 - Anmeldung vom 05.07.2017
keyboard_arrow_right 2016
-
2016-12-of 19 - => Individual proxy of 19-12-2016
-
2016-01-12 - Liste der Aufsichtsratsmitglieder zum 12.01.2016
-
2016-12-19 - Einzelvollmacht vom 19.12.2016
-
2016-12-19 - Dauervollmacht vom 19.12.2016
-
2016-01-12 - Anmeldung vom 12.01.2016
-
2016-02-04 - Anmeldung vom 04.02.2016
-
2016-05-24 - Anmeldung vom 24.05.2016
-
2016-12-om 19 - => Einzelvollmacht vom 19.12.2016
-
2016-01-20 - Amtsniederlegung vom 20.01.2016
keyboard_arrow_right 2015
-
2015-03-12 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 12.03.2015
-
2015-04-22 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 22.04.2015
-
2015-03-12 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 12.03.2015
-
2015-04-22 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 22.04.2015
-
2015-02-12 - Anmeldung vom 12.02.2015
-
2015-04-21 - Anmeldung vom 21.04.2015
-
2015-07-22 - Anmeldung vom 22.07.2015
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-11-17 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 17.11.2014
-
2014-11-17 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 17.11.2014
-
2014-12-19 - Anmeldung vom 19.12.2014
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-06-11 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 11.06.2013
-
2013-11-22 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 22.11.2013
-
2013-12-05 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 05.12.2013
-
2013-06-11 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 11.06.2013
-
2013-11-22 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 22.11.2013
-
2013-12-05 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 05.12.2013
-
2013-06-11 - Anmeldung vom 11.06.2013
-
2013-12-05 - Anmeldung vom 05.12.2013
-
2013-12-12 - Anmeldung vom 12.12.2013
-
2013-06-11 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 11.06.2013
-
2013-12-05 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 05.12.2013
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-11-02 - Unternehmensvertrag Umwandlungsvertrag sonstiger Vertrag vom 02.11.2012
-
2012-11-21 - Sonstige Urkunde Unterlage vom 21.11.2012
-
2012-02-03 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 03.02.2012
-
2012-03-09 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 09.03.2012
-
2012-11-21 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 21.11.2012
-
2012-11-26 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 26.11.2012
-
2012-11-of 02 - => Affiliation agreement - articles of conversion - other contracts of 02-11-2012
-
2012-11-02 - Affiliation agreement - articles of conversion - other contracts of 02-11-2012
-
2012-11-ed 26 - => Report - decision - record dated 26-11-2012
-
2012-11-ed 21 - => Report - decision - record dated 21-11-2012
-
2012-11-om 02 - => Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 02.11.2012
-
2012-11-02 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 02.11.2012
-
2012-11-21 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 21.11.2012
-
2012-11-om 26 - => Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 26.11.2012
-
2012-02-03 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 03.02.2012
-
2012-11-om 21 - => Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 21.11.2012
-
2012-03-09 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 09.03.2012
-
2012-11-21 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 21.11.2012
-
2012-11-26 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 26.11.2012
-
2012-02-20 - Anmeldung vom 20.02.2012
-
2012-04-20 - Anmeldung vom 20.04.2012
-
2012-11-26 - Anmeldung vom 26.11.2012
keyboard_arrow_right 2011
-
2011-12-15 - Unternehmensvertrag Umwandlungsvertrag sonstiger Vertrag vom 15.12.2011
-
2011-12-15 - Affiliation agreement - articles of conversion - other contracts of 15-12-2011
-
2011-12-15 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 15.12.2011
-
2011-12-15 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 15.12.2011
-
2011-12-22 - Liste der Ubernehmer vom 22.12.2011
-
2011-07-05 - Anmeldung vom 05.07.2011
-
2011-12-20 - Anmeldung vom 20.12.2011
-
2011-12-28 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 28.12.2011
-
2011-12-15 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 15.12.2011
keyboard_arrow_right 2010
-
2010-01-21 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 21.01.2010
-
2010-04-28 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 28.04.2010
-
2010-01-21 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 21.01.2010
-
2010-04-28 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 28.04.2010
-
2010-01-28 - Anmeldung vom 28.01.2010
-
2010-04-28 - Anmeldung vom 28.04.2010
-
2010-12-02 - Anmeldung vom 02.12.2010
-
2010-04-28 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 28.04.2010
keyboard_arrow_right 2009
-
2009-08-13 - Anmeldung vom 13.08.2009
-
2009-12-10 - Anmeldung vom 10.12.2009
keyboard_arrow_right 2007
-
2007-02-08 - Anmeldung vom 08.02.2007