-
-
RVT Process Equipment GmbH - Im Gries 15, 96364 Marktrodach, Germany
Company Information
- Company registration number
- HRB2695 COBURG
- Company Status
- LIVE
- Country
- Germany
- Registered Address
- Im Gries 15
- 96364 Marktrodach Im Gries 15, 96364 Marktrodach DE
Management
- Managing Directors
- Christian Geipel (Geschaeftsfuehrer)
- Werner Geipel (Geschaeftsfuehrer)
Company Details
- Type of Business
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Incorporated
- 1997-06-25
- Dissolved on
- -
- Age Of Company 1997-06-25 28 years
Ownership
- Share Capital
- 550.000,00 EUR
Jurisdiction Particularities
- Additional Status Details
- aktuell
- Court
- DE/Coburg
- Previous Names
- Rauschert Verfahrenstechnik GmbH
- Legal Entity Identifier (LEI)
- 5299007LAIX4L4P3M346
- VAT Number
- DE812042820
- Website
- https://www.rvtpe.com/global/de/
- Email address
- [email protected]
- Phone
- +49 9261552350
- Fax
- +49 926277789
-
RVT Process Equipment GmbH Company Description
- RVT Process Equipment GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Germany with the Company reg no HRB2695 COBURG. Its current trading status is "live". It was registered 1997-06-25. It was previously called Rauschert Verfahrenstechnik GmbH. The managing director is Christian Geipel,Werner Geipel.It can be contacted at Im Gries 15 by phone on +49 9261552350 by email at [email protected] by fax on +49 926277789 on the web at https://www.rvtpe.com/global/de/.
Get RVT Process Equipment GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract
You are here: Rvt Process Equipment Gmbh - Im Gries 15, 96364 Marktrodach, Germany
- 1997-06-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- years
-
Announcements from the Handelsregister
- 2022-01-20 Modification
- HRB *: RVT Process Equipment GmbH, Steinwiesen, Paul-Rauschert- Str. *, D-* Steinwiesen. Die Gesellschafterversammlung vom *.*.* hat die Änderung des § * (Firma und Sitz der Gesellschaft) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Sitz verlegt, nun: Neuer Sitz: Marktrodach. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Im Gries *, D-* Marktrodach. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dipl. Ing. Rüger, Herbert, Schneckenlohe, **.*.*.
-
RVT Process Equipment GmbH
Did you know? kompany provides original and official company documents for RVT Process Equipment GmbH as filed with the government register. Guaranteed.
Register Report
Official proof of the company existence
Shareholder List
Details on the shareholders
Articles of Association
Founding documents
Annual Account
Financial data for the last reported full year
Chronological Extract
Full record of registrable changes
Official Filings
Company filings direct from the official registry.
keyboard_arrow_down 2021
-
2021-11-11 - Anmeldung vom 11.11.2021
-
2021-04-28 - Anmeldung vom 28.04.2021
-
2021-11-11 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 11.11.2021
-
2021-04-28 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 28.04.2021
keyboard_arrow_right 2014
-
2014-12-10 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 10.12.2014
-
2014-12-10 - Affiliation agreement - articles of conversion - other contracts of 10-12-2014
-
2014-12-10 - Anmeldung vom 10.12.2014
-
2014-12-10 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 10.12.2014
-
2014-12-10 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 10.12.2014
-
2014-12-10 - Unternehmensvertrag Umwandlungsvertrag sonstiger Vertrag vom 10.12.2014
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-04-09 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 09.04.2013
-
2013-04-09 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 09.04.2013
-
2013-04-09 - Anmeldung vom 09.04.2013
-
2013-04-09 - Unternehmensvertrag Umwandlungsvertrag sonstiger Vertrag vom 09.04.2013
-
2013-05-22 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 22.05.2013
-
2013-04-09 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 09.04.2013
-
2013-05-22 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 22.05.2013
-
2013-05-22 - Anmeldung vom 22.05.2013
-
2013-05-22 - Affiliation agreement - articles of conversion - other contracts of 22-05-2013
-
2013-04-09 - Affiliation agreement - articles of conversion - other contracts of 09-04-2013
-
2013-05-22 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 22.05.2013
-
2013-06-13 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 13.06.2013
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-12-20 - Anmeldung vom 20.12.2012
keyboard_arrow_right 2013
-
2013-05-22 - Unternehmensvertrag Umwandlungsvertrag sonstiger Vertrag vom 22.05.2013
keyboard_arrow_right 2012
-
2012-10-04 - Unternehmensvertrag Umwandlungsvertrag sonstiger Vertrag vom 04.10.2012
-
2012-10-04 - Unternehmensvertrag - Umwandlungsvertrag - sonstiger Vertrag vom 04.10.2012
-
2012-12-20 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 20.12.2012
-
2012-10-04 - Affiliation agreement - articles of conversion - other contracts of 04-10-2012
-
2012-12-20 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 20.12.2012
-
2012-12-20 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 20.12.2012
keyboard_arrow_right 2008
-
2008-04-24 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 24.04.2008
-
2008-04-24 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 24.04.2008
-
2008-04-24 - Protokoll Beschluss Niederschrift vom 24.04.2008
-
2008-04-24 - Anmeldung vom 24.04.2008