• DE
  • WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH - Feldstr. 5, 06388 Köthen OT Baasdorf, Germany

Company Information

Company registration number
HRB11657 STENDAL
Company Status
LIVE
Country
Germany
Registered Address
Feldstr. 5
06388 Köthen OT Baasdorf
Feldstr. 5, 06388 Köthen OT Baasdorf DE

Management

Managing Directors
Leopold Graf von Drechsel (Geschaeftsfuehrer)
Ulrich Wagner (Geschaeftsfuehrer)
Ralph Weickert (Geschaeftsfuehrer)
Leopold von Drechsel (Geschaeftsfuehrer)

Company Details

Type of Business
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Incorporated
1993-02-02
Dissolved on
-
Age Of Company
1993-02-02 31 years

Ownership

Share Capital
4.522.800,00 DEM

Jurisdiction Particularities

Additional Status Details
aktuell
Court
DE/Stendal
Legal Entity Identifier (LEI)
529900ZEQBRYPOTHY595
VAT Number
DE133711077
Website
www.wimex-online.de/indexStart.html
email address
info@wimex-online.de
Phone
+49 349640030
Fax
+49 3496400330

WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH Company Description

WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH is a Gesellschaft mit beschränkter Haftung registered in Germany with the Company reg no HRB11657 STENDAL. Its current trading status is "live". It was registered 1993-02-02. The managing director is Leopold Graf von Drechsel,Ulrich Wagner,Ralph Weickert,Leopold von Drechsel.It can be contacted at Feldstr. 5 by phone on +49 349640030 by email at info@wimex-online.de by fax on +49 3496400330 on the web at www.wimex-online.de/indexStart.html.
More information

Get WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH Register ReportShareholder ListArticles of AssociationAnnual AccountChronological Extract

You are here: Wimex Agrarprodukte Import Und Export Gmbh - Feldstr. 5, 06388 Köthen OT Baasdorf, Germany

1993-02-02 31 years
  • 0-2
  • 3-5
  • 6-20
  • 21-50
  • 51+
  • years

Announcements from the Handelsregister

  • 2019-07-02 Modification
    • HRB *: WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH, Köthen, Feldstr. *, * Köthen OT Baasdorf. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wagner, Gerhard, Regenstauf. Bestellt: Geschäftsführer: Weickert, Ralph, Regenstauf, **.*.*, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Weickert, Ralph, Regenstauf, **.*.*.
    • 2019-05-09 Modification
      • HRB *: WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH, Köthen, Feldstr. *, * Köthen OT Baasdorf. Die Gesellschafterversammlung vom *.*.* hat die Änderung der §§ * (Geschäftsführung und Vertretung) und * (Beirat) der Satzung beschlossen.
    • 2015-10-05 Modification
      • HRB *: WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH, Baasdorf, Feldstraße *, * Baasdorf. Nach Gebietsreform von Amts wegen berichtigt, nun: Neuer Sitz: Köthen. Geschäftsanschrift: Feldstr. *, * Köthen OT Baasdorf.
  • Sign up to a plan to see the full content

    Did you know? kompany provides original and official company documents for WIMEX Agrarprodukte Import und Export GmbH as filed with the government register. Guaranteed.

    Add to Cart
     

    Register Report

    Official proof of the company existence

    Add to Cart
     

    Shareholder List

    Details on the shareholders

    Add to Cart
     

    Articles of Association

    Founding documents

    Add to Cart
     

    Annual Account

    Financial data for the last reported full year

    Add to Cart
     

    Chronological Extract

    Full record of registrable changes

    Official Filings

    Company filings direct from the official registry.

    • 2019-06-25 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 25.06.2019

      Add to Cart
       
    • 2019-06-25 - Anmeldung vom 25.06.2019

      Add to Cart
       
    • 2019-03-28 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 28.03.2019

      Add to Cart
       
    • 2019-03-28 - Anmeldung vom 28.03.2019

      Add to Cart
       
    • 2019-05-08 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 08.05.2019

      Add to Cart
       
    • 2013-01-23 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 23.01.2013

      Add to Cart
       
    • 2011-08-12 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 12.08.2011

      Add to Cart
       
    • 2011-01-11 - Liste der Gesellschafter - Aufnahme in den Registerordner am 11.01.2011

      Add to Cart
       
    • 2015-09-28 - Anmeldung vom 28.09.2015

      Add to Cart
       
    • 2015-09-17 - Anmeldung vom 17.09.2015

      Add to Cart
       
    • 2011-05-05 - Anmeldung vom 05.05.2011

      Add to Cart
       
    • 2011-04-06 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 06.04.2011

      Add to Cart
       
    • 2011-03-31 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 31.03.2011

      Add to Cart
       
    • 2011-04-05 - Sonstige Urkunde - Unterlage vom 05.04.2011

      Add to Cart
       
    • 2010-07-21 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 21.07.2010

      Add to Cart
       
    • 2010-07-21 - Anmeldung vom 21.07.2010

      Add to Cart
       
    • 2007-12-17 - Gesellschaftsvertrag - Satzung - Statut vom 17.12.2007

      Add to Cart
       
    • 2007-12-17 - Protokoll - Beschluss - Niederschrift vom 17.12.2007

      Add to Cart
       
    • 2007-12-17 - Anmeldung vom 17.12.2007

      Add to Cart
       
    expand_less